-
UK FREIGHT MASTERS LIMITED - Centrum West, Callister Way, Burton-On-Trent, DE14 2SY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09496181
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Centrum West
- Callister Way
- Burton-On-Trent
- DE14 2SY
- England Centrum West, Callister Way, Burton-On-Trent, DE14 2SY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- EGGLETON, Ross David
- SURGEY, Samantha Marion
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-18 9 Jahre
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ANSONSCO 1 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-01
- Letzte Einreichung: 2021-03-18
-
UK FREIGHT MASTERS LIMITED Firmenbeschreibung
- UK FREIGHT MASTERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09496181. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2015 registriert. UK FREIGHT MASTERS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ANSONSCO 1 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Centrum West erreicht werden.
Jetzt sichern UK FREIGHT MASTERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Uk Freight Masters Limited - Centrum West, Callister Way, Burton-On-Trent, DE14 2SY, Grossbritannien
- 2015-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UK FREIGHT MASTERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-05) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-05) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-05) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2020-01-20) - SH01
-
resolution (2020-01-20) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-01-20) - SH02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-06-24) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-09) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-10) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-06) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-06) - PSC02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-10-07) - AP03
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-23) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-07-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-10) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-05-13) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-10) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-23) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-23) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-24) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-25) - MR01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2019-10-25) - RP04AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-07-23) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-07-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-28) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-31) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
-
resolution (2016-05-19) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-06-13) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-17) - TM01
-
incorporation-company (2015-03-18) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-17) - AP03