-
THREAD 35 LTD - 40 Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09491272
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40 Water Lane
- Wilmslow
- Cheshire
- SK9 5AP
- England 40 Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DILKS, Stephen James
- HALL, Alison Sarah
- LAVINGTON, Julie Christina
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-16 9 Jahre
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sosandar Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800PP3JICU9KKUN43
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-16
- Letzte Einreichung: 2023-03-02
-
THREAD 35 LTD Firmenbeschreibung
- THREAD 35 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09491272. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 40 Water Lane erreicht werden.
Jetzt sichern THREAD 35 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Thread 35 Ltd - 40 Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AP, Grossbritannien
- 2015-03-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THREAD 35 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-01) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-10-23) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-09) - MR01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-12) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-13) - PSC08
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-11-15) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-11-17) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-12) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-17) - PSC02
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-14) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-09) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-12) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-04-14) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-01-22) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-04-25) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-08-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-09) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-10-09) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-10-09) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-09) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-10-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-09) - TM01
-
incorporation-company (2015-03-16) - NEWINC