-
SPIRIT OF 48 LIMITED - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09487962
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Radian Court
- Knowlhill
- Milton Keynes
- Buckinghamshire
- MK5 8PJ 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK5 8PJ UK
Management
- Geschäftsführung
- MUNRO, Andrew Ross
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-13 9 Jahre
- SIC/NACE
- 45112
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Arm Automotive Yorkshire Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Ehemalige Namen
- LR MOTORS (YORKSHIRE) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-27
- Letzte Einreichung: 2022-03-13
-
SPIRIT OF 48 LIMITED Firmenbeschreibung
- SPIRIT OF 48 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09487962. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.03.2015 registriert. SPIRIT OF 48 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LR MOTORS (YORKSHIRE) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45112" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 Radian Court erreicht werden.
Jetzt sichern SPIRIT OF 48 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Spirit Of 48 Limited - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2015-03-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPIRIT OF 48 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-in-administration-proposals (2023-05-20) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-20) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2023-01-20) - CERTNM
-
liquidation-in-administration-proposals (2023-05-18) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-04-08) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2023-04-08) - AM01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-10-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-01-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-28) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-28) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-02-02) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-26) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-28) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-29) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-21) - CH01
-
resolution (2020-01-16) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-06) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-17) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-17) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-10-24) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-09-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-08-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-08-25) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-25) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-09) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-09) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-09) - CH01
-
incorporation-company (2015-03-13) - NEWINC