-
APRIL TOPCO LIMITED - Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09484023
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Central Square
- 29 Wellington Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 4DL Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4DL UK
Management
- Geschäftsführung
- WARDROP, William Andrew
- APRIL MIDCO LIMITED
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2015
- Gelöscht am:
- 2022-10-26
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Eci Partners Llp
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- April Topco Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- AGHOCO 1290 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-07-31
- Letzte Einreichung: 2017-10-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-25
- Letzte Einreichung: 2018-03-11
-
APRIL TOPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- APRIL TOPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09484023. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.03.2015 registriert. APRIL TOPCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGHOCO 1290 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Central Square erreicht werden.
Jetzt sichern APRIL TOPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: April Topco Limited - Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu APRIL TOPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2022-07-26) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2022-10-26) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-31) - 600
-
resolution (2019-07-31) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-08) - AD01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-07-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2019-05-22) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-08) - AP01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-07-31) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-07-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-01) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-01) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-07-19) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-05-24) - SH01
-
resolution (2017-04-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-08-05) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-08-01) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-01) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-01) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-21) - AP01
-
resolution (2016-06-10) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-05-31) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-05-27) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-27) - AP01
-
resolution (2015-05-27) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-27) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-06) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-27) - AP03
-
capital-allotment-shares (2015-05-27) - SH01
-
incorporation-company (2015-03-11) - NEWINC
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-05-27) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-29) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-06-30) - SH01
-
resolution (2015-07-07) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2015-07-07) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-08-14) - SH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-06) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-05-27) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-07) - CERTNM