-
ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED - 12 Mill Hill, Leeds, LS1 5DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09473869
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 Mill Hill
- Leeds
- LS1 5DQ 12 Mill Hill, Leeds, LS1 5DQ UK
Management
- Geschäftsführung
- HAMMERSLEY, Mark Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2015
- Gelöscht am:
- 2021-10-14
- SIC/NACE
- 70100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- AQUA BIDCO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-16
- Letzte Einreichung: 2020-03-05
-
ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09473869. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.03.2015 registriert. ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AQUA BIDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 12 Mill Hill erreicht werden.
Jetzt sichern ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Zoggs Acquisitions Limited - 12 Mill Hill, Leeds, LS1 5DQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ZOGGS ACQUISITIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-02-10) - AM10
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2020-10-16) - AM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-10) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-05-29) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-05-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-30) - TM01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2020-07-22) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-03) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2020-09-21) - AM03
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-04) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-29) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2016-03-29) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-29) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-10) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-03-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-06) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-19) - AP03
-
incorporation-company (2015-03-05) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2015-04-14) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2015-05-20) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-19) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-14) - CERTNM