-
WL ONE BIDCO LIMITED - Horizon, Honey Lane, Hurley, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09415478
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Horizon
- Honey Lane
- Hurley
- Berkshire
- SL6 6RJ
- England Horizon, Honey Lane, Hurley, Berkshire, SL6 6RJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MILLER, Richard
- TUCKER, Oliver Robert Stewart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64205
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- Wl One Midco 2 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800Z6HZR5MEF59S54
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-23
- Letzte Einreichung: 2023-05-09
-
WL ONE BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- WL ONE BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09415478. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64205" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Horizon erreicht werden.
Jetzt sichern WL ONE BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wl One Bidco Limited - Horizon, Honey Lane, Hurley, Berkshire, Grossbritannien
- 2015-01-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WL ONE BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-19) - CS01
-
legacy (2023-02-02) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-02-02) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-02-02) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-02-02) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-07-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
legacy (2022-02-03) - AGREEMENT2
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-07-27) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-03-10) - AA
-
legacy (2022-03-10) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-23) - CS01
-
legacy (2022-02-03) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-02-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-25) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-22) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-03) - PSC01
-
capital-allotment-shares (2018-03-07) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-21) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-25) - CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2018-03-05) - RP04SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-13) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-05-14) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-17) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-04) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-13) - AP01
-
incorporation-company (2015-01-30) - NEWINC
-
resolution (2015-03-17) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-04) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-03-02) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-02-26) - AA01