-
LEISURE & DEVELOPMENT LIMITED - C/O Rsm Restructuring Advisory Llp St Philips Point, Temple Row, Birmingham, B2 5AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09395012
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Rsm Restructuring Advisory Llp St Philips Point
- Temple Row
- Birmingham
- B2 5AF C/O Rsm Restructuring Advisory Llp St Philips Point, Temple Row, Birmingham, B2 5AF UK
Management
- Geschäftsführung
- HEER, Sukhbinder Singh
- PARTDRIDGE, Keith Harvey
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-19 9 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Harvey Partdridge
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-07
- Letzte Einreichung: 2018-07-24
-
LEISURE & DEVELOPMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- LEISURE & DEVELOPMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09395012. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Rsm Restructuring Advisory Llp St Philips Point erreicht werden.
Jetzt sichern LEISURE & DEVELOPMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Leisure & Development Limited - C/O Rsm Restructuring Advisory Llp St Philips Point, Temple Row, Birmingham, B2 5AF, Grossbritannien
- 2015-01-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LEISURE & DEVELOPMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-02-20) - AM10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-03-08) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-08-22) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-07-05) - AM19
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-10-05) - AM06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-26) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-30) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-30) - MR01
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-09-20) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-08-18) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-13) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-24) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-30) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-11) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2017-02-17) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-03) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-16) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-18) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-17) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-13) - MR01
-
incorporation-company (2015-01-19) - NEWINC