-
MEDSOLVE (UK) LIMITED - 172 Front Street, Chester Le Street, DH3 3AZ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09390744
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 172 Front Street
- Chester Le Street
- DH3 3AZ
- England 172 Front Street, Chester Le Street, DH3 3AZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BAHIA, Sat Singh
- DAY, Jonathan Paul
- DODDS, Lisa
- RAMSAY, James
- RICHARDSON, Ian Ashley
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-15 9 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian Ashley Richardson
- Dr Magdy Adib Ishak-Hanna
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-29
- Letzte Einreichung: 2021-01-15
-
MEDSOLVE (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- MEDSOLVE (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09390744. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 172 Front Street erreicht werden.
Jetzt sichern MEDSOLVE (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Medsolve (Uk) Limited - 172 Front Street, Chester Le Street, DH3 3AZ, England, Grossbritannien
- 2015-01-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEDSOLVE (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-10) - AA
-
memorandum-articles (2021-07-05) - MA
-
resolution (2021-07-05) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-10) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-09-14) - PSC04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-28) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-18) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-07) - AA
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-01-16) - AD03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-15) - CS01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-01-15) - AD02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-03) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-21) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-05-01) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-04-21) - SH08
-
resolution (2015-04-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-04-08) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2015-02-11) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-11) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-27) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-01-27) - AA01
-
incorporation-company (2015-01-15) - NEWINC