-
PROCENSUS LIMITED - C/O Valentine & Co Glade House 52-54, Carter Lane, London, EC4V 5EF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09384818
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Valentine & Co Glade House 52-54
- Carter Lane
- London
- EC4V 5EF C/O Valentine & Co Glade House 52-54, Carter Lane, London, EC4V 5EF UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLCHIN, Edward Michael
- ALLCHIN, James William Harold
- FIRKINS, Jonathan
- MCGRANAHAN, Colin
- WALMSLEY, Alastair
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-12 9 Jahre
- SIC/NACE
- 58290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- CENSUZ LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-26
- Letzte Einreichung: 2021-01-12
-
PROCENSUS LIMITED Firmenbeschreibung
- PROCENSUS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09384818. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.01.2015 registriert. PROCENSUS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CENSUZ LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58290" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Valentine & Co Glade House 52-54 erreicht werden.
Jetzt sichern PROCENSUS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Procensus Limited - C/O Valentine & Co Glade House 52-54, Carter Lane, London, EC4V 5EF, Grossbritannien
- 2015-01-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROCENSUS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-30) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-08-10) - SH01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-09-11) - 600
-
resolution (2021-09-11) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-09-11) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-allotment-shares (2020-04-17) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-28) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-03-02) - PSC08
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2020-05-28) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-29) - TM01
-
capital-allotment-shares (2019-01-10) - SH01
-
capital-allotment-shares (2019-09-10) - SH01
-
resolution (2019-09-16) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-08-01) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-07-03) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-20) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-01-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-26) - AA
-
legacy (2017-09-18) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-29) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-15) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-03-16) - SH01
-
resolution (2015-05-18) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-01-12) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2015-05-18) - SH01
-
resolution (2015-09-09) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-09-09) - SH02
-
capital-allotment-shares (2015-09-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-09) - AP01
-
resolution (2015-10-14) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-27) - AP01
-
legacy (2015-10-14) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-10-14) - SH19
-
legacy (2015-10-14) - SH20
-
change-of-name-notice (2015-12-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-10) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2015-10-12) - SH01
-
resolution (2015-02-27) - RESOLUTIONS