-
SG2HC LTD - 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09372967
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 264 Banbury Road
- Oxford
- OX2 7DY 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY UK
Management
- Geschäftsführung
- BUCHHOLZ, Lynne Fiona
- DANIELS, Samantha Jane
- EDGAR-GIBSON, Edward Brian
- GARDENER, Sarah Anne
- NEAL, Stephen Howard
- O'CONNELL, Peter
- RICKWOOD, David John Francis
- SIMMONS, Hayley Dawn
- SMITH, Leigh Robin
- WATSON, Lorna
- WATTS, Peter John
- WETHERALL, Stephen John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.01.2015
- Alter der Firma 2015-01-05 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-29
- Letzte Einreichung: 2020-05-15
-
SG2HC LTD Firmenbeschreibung
- SG2HC LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09372967. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.01.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 12 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 264 Banbury Road erreicht werden.
Jetzt sichern SG2HC LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sg2Hc Ltd - 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY, Grossbritannien
- 2015-01-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SG2HC LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-01) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2019-03-15) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-03-26) - SH03
-
capital-allotment-shares (2019-04-05) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-15) - AA
-
capital-cancellation-shares (2019-04-16) - SH06
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-15) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-15) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-15) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-15) - CH01
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-04-16) - SH03
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-08) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-09) - CS01
-
resolution (2018-02-08) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-02-09) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2018-02-09) - SH06
-
resolution (2018-02-09) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-02-12) - SH10
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-19) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-02-12) - SH08
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-07-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-18) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-09-02) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-07-24) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-07-24) - SH10
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-05) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-08) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-02-16) - SH03
-
resolution (2016-02-16) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2016-02-16) - SH06
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-08) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-24) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-24) - AD01
-
capital-allotment-shares (2015-03-24) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-03-24) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-03-24) - SH08
-
resolution (2015-03-24) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-15) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-20) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-22) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-12-22) - AA01
-
incorporation-company (2015-01-05) - NEWINC