-
AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED - 7 A/B, Millington Road, Hayes, Middlesex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09358935
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7 A/B
- Millington Road
- Hayes
- Middlesex
- UB3 4AZ
- England 7 A/B, Millington Road, Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CAFFYN, Andrew David
- FANNING, Alastair Scott
- RICHARDS, Catherine Allingham
- SPENCER-CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
- VILLAGARCIA ITURRIONDO, Inigo
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Avantus Aerospace Holdco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SHIMTECH INDUSTRIES HOLDCO2 LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800NDQN18XG4W5M21
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-15
- Letzte Einreichung: 2023-04-01
-
AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED Firmenbeschreibung
- AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09358935. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.12.2014 registriert. AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SHIMTECH INDUSTRIES HOLDCO2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 7 A/b erreicht werden.
Jetzt sichern AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Avantus Aerospace Holdco2 Limited - 7 A/B, Millington Road, Hayes, Middlesex, Grossbritannien
- 2014-12-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AVANTUS AEROSPACE HOLDCO2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-20) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-07-07) - MR01
-
capital-allotment-shares (2023-07-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-04-06) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2022-04-12) - AAMD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-07-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-01) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-01) - PSC05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-01) - MR01
-
resolution (2020-02-26) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-05-15) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-18) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-11-29) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-08) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-13) - AA
-
change-of-name-notice (2017-05-04) - CONNOT
-
resolution (2017-05-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-02-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-21) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-28) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-29) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-09-01) - SH02
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-01-19) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-06) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-07-08) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-24) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-19) - CERTNM
-
incorporation-company (2014-12-17) - NEWINC