-
P&S ACQUISITIONS LIMITED - 130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor, London, W1D 5EU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09358914
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 130 Shaftesbury Avenue
- 2nd Floor
- London
- W1D 5EU
- United Kingdom 130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor, London, W1D 5EU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DALDRY, Doug
- NEVILLE, Micheal
- SEXTON, Stuart Andrew
- SIDHU, Gurmai
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Doug Daldry
- Mr Keith Harris
- Gary Martin
- Socius Investments Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-14
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
-
P&S ACQUISITIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- P&S ACQUISITIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09358914. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 130 Shaftesbury Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern P&S ACQUISITIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: P&s Acquisitions Limited - 130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor, London, W1D 5EU, Grossbritannien
- 2014-12-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu P&S ACQUISITIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-02) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-07-24) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-24) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-07-24) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-07-16) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-24) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-27) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-06) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-15) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-15) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-18) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2019-09-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-03-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-03-12) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-19) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-18) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-04-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-17) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-05) - MR01
-
capital-allotment-shares (2016-04-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-10) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-03-16) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-12) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-25) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-07-10) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-04-20) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-12-15) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-12-17) - SH02
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-17) - NEWINC