-
SCP ACQUISITION BIDCO LIMITED - 25 Argyll Street, London, W1F 7TU, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09353444
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Argyll Street
- London
- W1F 7TU
- England 25 Argyll Street, London, W1F 7TU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BLEAKLEY, Tim James
- JOSEPH, Stephen Zev
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-12 9 Jahre
- SIC/NACE
- 73110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Atoll Debtco Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800ME5B5WTBAPPP73
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-14
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
-
SCP ACQUISITION BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- SCP ACQUISITION BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09353444. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 Argyll Street erreicht werden.
Jetzt sichern SCP ACQUISITION BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Scp Acquisition Bidco Limited - 25 Argyll Street, London, W1F 7TU, England, Grossbritannien
- 2014-12-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SCP ACQUISITION BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-05) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-09-26) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-07-20) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-07-20) - SH19
-
legacy (2020-07-20) - CAP-SS
-
resolution (2020-07-20) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-11-05) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-03-20) - SH01
-
resolution (2019-03-22) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-06-20) - SH01
-
resolution (2019-06-24) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-16) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-11-05) - SH19
-
legacy (2019-11-05) - CAP-SS
-
legacy (2019-11-05) - SH20
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-19) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-06-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-18) - TM01
-
capital-allotment-shares (2018-10-02) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-18) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-02) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-03) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-02-09) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-22) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-03) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-23) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-01-27) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-11) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-24) - MR01
-
incorporation-company (2014-12-12) - NEWINC