-
SHG (CARE VILLAGES) LIMITED - 2, Fusion Court, Aberford Road, Garforth, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09349619
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2
- Fusion Court
- Aberford Road
- Garforth
- Leeds
- LS25 2GH 2, Fusion Court, Aberford Road, Garforth, Leeds, LS25 2GH UK
Management
- Geschäftsführung
- JACKSON, Timothy Roger
- LEE, Graeme
- PHILLIPS, Paul Rodney
- RIGBY, Mark Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-10 9 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Graeme Stuart Lee
- -
- Business Growth Fund Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-21
- Letzte Einreichung: 2019-12-10
-
SHG (CARE VILLAGES) LIMITED Firmenbeschreibung
- SHG (CARE VILLAGES) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09349619. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 erreicht werden.
Jetzt sichern SHG (CARE VILLAGES) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Shg (Care Villages) Limited - 2, Fusion Court, Aberford Road, Garforth, Grossbritannien
- 2014-12-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SHG (CARE VILLAGES) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-16) - AA
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2020-09-18) - RP04AR01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-27) - PSC07
-
resolution (2019-03-19) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-30) - PSC01
-
resolution (2019-07-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-21) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-28) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-31) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-12-17) - AA
-
resolution (2018-11-06) - RESOLUTIONS
-
resolution (2018-08-20) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-22) - MR01
-
resolution (2018-03-13) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-22) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-12) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-12) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-05) - AP01
-
resolution (2016-06-13) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-20) - MR01
-
resolution (2016-01-06) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-11-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-12-31) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-12-31) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-12) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-04-14) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-04-14) - SH02
-
resolution (2015-02-25) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-12-10) - AA01
-
incorporation-company (2014-12-10) - NEWINC