-
FMG FINANCE LIMITED - Broad Lea House Dyson Wood Way, Bradley, Huddersfield, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09347579
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Broad Lea House Dyson Wood Way
- Bradley
- Huddersfield
- West Yorkshire
- HD2 1GZ
- England Broad Lea House Dyson Wood Way, Bradley, Huddersfield, West Yorkshire, HD2 1GZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- OWENS, Claire
- WARD, Martin
- STEAD, Paul Harvey
- VINCENT, Philip James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-09 9 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Fmg Group Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BIDCO FLAMINGO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-23
- Letzte Einreichung: 2020-12-09
-
FMG FINANCE LIMITED Firmenbeschreibung
- FMG FINANCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09347579. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.12.2014 registriert. FMG FINANCE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BIDCO FLAMINGO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Broad Lea House Dyson Wood Way erreicht werden.
Jetzt sichern FMG FINANCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fmg Finance Limited - Broad Lea House Dyson Wood Way, Bradley, Huddersfield, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2014-12-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FMG FINANCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-02-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-31) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-04-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-03-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-03-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-04) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-09) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-18) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-04) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-06-01) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-06-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-06-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-28) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-14) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-17) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-20) - AP01
-
resolution (2015-04-27) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-04-28) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-23) - CERTNM
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-28) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-07-28) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-28) - AP01
-
change-of-name-notice (2015-06-23) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-12) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-12) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-12) - AP01
-
incorporation-company (2014-12-09) - NEWINC