-
CALDIC INGREDIENTS UK LTD. - Hitec House Sand Road Industrial Estate, Caxton Road, Great Gransden, Bedfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09345197
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hitec House Sand Road Industrial Estate
- Caxton Road
- Great Gransden
- Bedfordshire
- SG19 3AH Hitec House Sand Road Industrial Estate, Caxton Road, Great Gransden, Bedfordshire, SG19 3AH UK
Management
- Geschäftsführung
- EBANKS, Richard Lawrence
- HODKIN-LAWTON, John
- PASQUALINI, Laurent Armando Franco
- ZEMP, Martin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-08 9 Jahre
- SIC/NACE
- 10860
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Caldic (Uk) Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- Caldic Ingredients UK Ltd.
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FOOD INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED
- UID/USt-ID-Nummer
- GB219035133
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-22
- Letzte Einreichung: 2023-12-08
-
CALDIC INGREDIENTS UK LTD. Firmenbeschreibung
- CALDIC INGREDIENTS UK LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09345197. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.12.2014 registriert. CALDIC INGREDIENTS UK LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FOOD INDUSTRY TECHNOLOGY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10860" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hitec House Sand Road Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern CALDIC INGREDIENTS UK LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Caldic Ingredients Uk Ltd. - Hitec House Sand Road Industrial Estate, Caxton Road, Great Gransden, Bedfordshire, Grossbritannien
- 2014-12-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CALDIC INGREDIENTS UK LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-11) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2023-09-01) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-09-01) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-06-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-05) - CS01
-
certificate-change-of-name-company (2023-09-01) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-08-15) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-31) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-05-31) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-05-31) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-05-31) - PSC02
-
resolution (2022-05-23) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-05-19) - RP04CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-05-18) - PSC01
-
capital-allotment-shares (2022-05-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-18) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-18) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-12-18) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-08) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-22) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-12-08) - CH03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-09) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-08) - NEWINC