-
ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED - Suite A 7th Floor East West Building, 2 Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09344283
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite A 7th Floor East West Building
- 2 Tollhouse Hill
- Nottingham
- NG1 5FS Suite A 7th Floor East West Building, 2 Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS UK
Management
- Geschäftsführung
- BALDRY, Michael Terence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.12.2014
- Gelöscht am:
- 2023-04-09
- SIC/NACE
- 45190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Terence Baldry
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- THE LACE MARKET HOTEL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-10
- Letzte Einreichung: 2018-02-24
-
ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED Firmenbeschreibung
- ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09344283. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.12.2014 registriert. ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE LACE MARKET HOTEL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45190" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite A 7Th Floor East West Building erreicht werden.
Jetzt sichern ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Abacus Motor Company Limited - Suite A 7th Floor East West Building, 2 Tollhouse Hill, Nottingham, NG1 5FS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ABACUS MOTOR COMPANY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-01-09) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-04-09) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-03) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-09-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-11) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-12-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-12-20) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-06-04) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-06-04) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-01) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-01) - 600
-
resolution (2018-09-01) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-21) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-12-29) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-02-21) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-08-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-16) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-01) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-01) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-04-21) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-08) - NEWINC