-
JCP SOLICITORS LIMITED - Venture Court Waterside Business Park, Valley Way, Enterprise Park, Swansea, SA6 8AH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09336286
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Venture Court Waterside Business Park
- Valley Way, Enterprise Park
- Swansea
- SA6 8AH
- Wales Venture Court Waterside Business Park, Valley Way, Enterprise Park, Swansea, SA6 8AH, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Christopher Wayne
- DAVIES, Hayley
- DAVIES, John Peter
- GILROY, Emma Frances
- HOWELLS, Richard Glyn
- HUTCHINGS, Rory Kerr
- JACKSON-THOMAS, Sarah Jane
- MORGAN, Lynne
- OWEN, Matthew James
- POWELL, Betsan Wyn
- SEPPMAN, Amy Kate
- SHAW, Christopher
- THOMAS, Keith
- WILLIAMS, Michael Kenneth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-02 9 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-13
- Letzte Einreichung: 2019-12-02
-
JCP SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- JCP SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09336286. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.12.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 14 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Venture Court Waterside Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern JCP SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jcp Solicitors Limited - Venture Court Waterside Business Park, Valley Way, Enterprise Park, Swansea, SA6 8AH, Grossbritannien
- 2014-12-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JCP SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
memorandum-articles (2020-08-27) - MA
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-01-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-07-27) - SH01
-
resolution (2020-08-27) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-09) - CS01
-
resolution (2019-05-16) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-04-30) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-30) - AP01
-
capital-cancellation-shares (2019-04-25) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-04-25) - SH03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-05) - CH01
-
capital-allotment-shares (2018-12-13) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-15) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-12-31) - SH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-05) - AD01
-
capital-cancellation-shares (2018-12-31) - SH06
-
resolution (2018-12-31) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-03-09) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-03-13) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-25) - AP01
-
memorandum-articles (2017-05-05) - MA
-
resolution (2017-05-15) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-05-31) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-11) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-11-15) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-12-01) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-06-09) - AA01
-
legacy (2016-07-15) - RPCH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-02) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-01) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-20) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-02) - NEWINC