-
54E STREET LIMITED - 9 Thorney Leys Park, Witney, Oxfordshire, OX28 4GE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09330098
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Thorney Leys Park
- Witney
- Oxfordshire
- OX28 4GE 9 Thorney Leys Park, Witney, Oxfordshire, OX28 4GE UK
Management
- Geschäftsführung
- BOLAH, Kelvin
- HOLLAND, Gregory Francis
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.11.2014
- Gelöscht am:
- 2021-07-06
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gregory Francis Holland
- Mr Kelvin Bolah
- Mr Kelvin Bolah
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-11-30
- Letzte Einreichung: 2018-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-18
- Letzte Einreichung: 2020-08-04
-
54E STREET LIMITED Firmenbeschreibung
- 54E STREET LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09330098. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 27.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 9 Thorney Leys Park erreicht werden.
Jetzt sichern 54E STREET LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 54E Street Limited - 9 Thorney Leys Park, Witney, Oxfordshire, OX28 4GE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 54E STREET LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-02-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-29) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-02) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-17) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-03-16) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-15) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-15) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-03-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-10) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-26) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-11-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-06) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-08) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-02) - AP01
-
incorporation-company (2014-11-27) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2014-12-02) - SH01