-
ISUPPLY DRIVERS LIMITED - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09313322
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Riverside House
- Irwell Street
- Manchester
- M3 5EN Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN UK
Management
- Geschäftsführung
- LEWIS, Stephen David
- PISARSKI, Marcin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Marcin Pisarski
- Mr Stephen David Lewis
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-16
- Letzte Einreichung: 2022-11-02
-
ISUPPLY DRIVERS LIMITED Firmenbeschreibung
- ISUPPLY DRIVERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09313322. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.11.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Riverside House erreicht werden.
Jetzt sichern ISUPPLY DRIVERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Isupply Drivers Limited - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
- 2014-11-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ISUPPLY DRIVERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2023-02-13) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-15) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2023-04-04) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2023-04-18) - AM06
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2023-05-20) - AM02
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-22) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-22) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-08) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-06) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-11-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-22) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-07) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-10) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-17) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-06) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-29) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-11-17) - NEWINC