-
SEAFOX WARWICK 1 LIMITED - 1 Mercer Street, London, WC2H 9QJ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09306591
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Mercer Street
- London
- WC2H 9QJ
- England 1 Mercer Street, London, WC2H 9QJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ABRAHAMS, Iain Henry
- NICHOLSON, George Elliott
- SCHMIDT-CHIARI, Stanislaus Eduard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-12 9 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Longacre Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- SEAFOX VFE 1 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-15
- Letzte Einreichung: 2023-10-01
-
SEAFOX WARWICK 1 LIMITED Firmenbeschreibung
- SEAFOX WARWICK 1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09306591. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.11.2014 registriert. SEAFOX WARWICK 1 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SEAFOX VFE 1 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 Mercer Street erreicht werden.
Jetzt sichern SEAFOX WARWICK 1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Seafox Warwick 1 Limited - 1 Mercer Street, London, WC2H 9QJ, England, Grossbritannien
- 2014-11-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SEAFOX WARWICK 1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-11-28) - AA
-
legacy (2023-11-28) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-11-28) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-01-11) - AA
-
legacy (2023-01-11) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-11-28) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-01-11) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-01-11) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-14) - CS01
-
resolution (2021-08-18) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-08-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-03-10) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-02-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC02
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-11-26) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-10) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-26) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-26) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-03-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-06) - CH01
-
resolution (2018-07-05) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-03-27) - MA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-11-20) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-27) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-24) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-20) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-04-09) - SH02
-
memorandum-articles (2017-03-31) - MA
-
resolution (2017-03-31) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-08-10) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-21) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-17) - AA
-
termination-director-company (2016-01-19) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-05) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-18) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-21) - AD01
-
incorporation-company (2014-11-12) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-19) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-12-19) - SH01