-
PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD - Unit 2b1 Seacroft Industrial Estate, Coal Road, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09295298
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2b1 Seacroft Industrial Estate
- Coal Road
- Leeds
- West Yorkshire
- LS14 2AQ
- England Unit 2b1 Seacroft Industrial Estate, Coal Road, Leeds, West Yorkshire, LS14 2AQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GULLIVER, Alan
- GULLIVER, Joanne
- WOODS, Nigel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.11.2014
- Alter der Firma 2014-11-04 9 Jahre
- SIC/NACE
- 16230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alan Gulliver
- Mr Alan Gulliver
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- PROTECH SYSTEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-14
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
-
PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD Firmenbeschreibung
- PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09295298. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.11.2014 registriert. PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PROTECH SYSTEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "16230" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 2B1 Seacroft Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Protech Timber Engineering Ltd - Unit 2b1 Seacroft Industrial Estate, Coal Road, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2014-11-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROTECH TIMBER ENGINEERING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-29) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-05-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-13) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-10-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-03-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-06) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-17) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-17) - CS01
-
resolution (2017-10-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-02-09) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-16) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-17) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-03) - AD01
-
incorporation-company (2014-11-04) - NEWINC