-
CCI HOLDINGS LTD - Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09290253
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cvr Global Llp
- 20 Furnival Street
- London
- EC4A 1JQ Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BLOUNT, Mark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-31 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64205
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Ms Puspa Varsani
- Mr Mark Blount
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- COPPERCAST LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-01-31
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-22
- Letzte Einreichung: 2018-11-08
-
CCI HOLDINGS LTD Firmenbeschreibung
- CCI HOLDINGS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09290253. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.10.2014 registriert. CCI HOLDINGS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COPPERCAST LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64205" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Cvr Global Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CCI HOLDINGS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cci Holdings Ltd - Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ, Grossbritannien
- 2014-10-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CCI HOLDINGS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-08-24) - WU07
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-08-25) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2019-07-17) - WU04
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2019-03-28) - COCOMP
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-12) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-13) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-23) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-23) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-11) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-02) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-07) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-08) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-08) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-02) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-12) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-28) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-28) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-28) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-28) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-28) - PSC07
-
resolution (2018-07-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-10-17) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-12) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-02) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-31) - NEWINC