-
PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED - Unit A Victoria Court, 21 - 25 Tennant Street, Nuneaton, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09275304
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit A Victoria Court
- 21 - 25 Tennant Street
- Nuneaton
- Warwickshire
- CV11 4LZ
- England Unit A Victoria Court, 21 - 25 Tennant Street, Nuneaton, Warwickshire, CV11 4LZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NEALE, Jack
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-22 9 Jahre
- SIC/NACE
- 43910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian Neale
- Mr Jack Neale
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PREMIER REFURB SYSTEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-08-31
- Letzte Einreichung: 2019-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-05
- Letzte Einreichung: 2020-10-22
-
PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED Firmenbeschreibung
- PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09275304. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.10.2014 registriert. PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PREMIER REFURB SYSTEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43910" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit A Victoria Court erreicht werden.
Jetzt sichern PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Premibuild (Midlands) Limited - Unit A Victoria Court, 21 - 25 Tennant Street, Nuneaton, Warwickshire, Grossbritannien
- 2014-10-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREMIBUILD (MIDLANDS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-18) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-04-17) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-17) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-04-17) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-17) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-17) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-01) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-22) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-29) - AA
-
resolution (2019-04-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-27) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-27) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
-
resolution (2016-06-20) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-30) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-07) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-19) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-04) - CS01
-
resolution (2016-07-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-29) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-11-26) - AA01
-
incorporation-company (2014-10-22) - NEWINC