-
TRS BARS AND RESTAURANTS LIMITED - Haslers Hawke House, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09269328
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Haslers Hawke House
- Old Station Road
- Loughton
- Essex
- IG10 4PL
- United Kingdom Haslers Hawke House, Old Station Road, Loughton, Essex, IG10 4PL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- SHIPTON, Matthew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-17 9 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Wendy Shipton
- Mr Matthew Shipton
- -
- Mr Matthew Shipton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-07-31
- Letzte Einreichung: 2021-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-03
- Letzte Einreichung: 2023-03-20
-
TRS BARS AND RESTAURANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- TRS BARS AND RESTAURANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09269328. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Haslers Hawke House erreicht werden.
Jetzt sichern TRS BARS AND RESTAURANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trs Bars And Restaurants Limited - Haslers Hawke House, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
- 2014-10-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRS BARS AND RESTAURANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-09-29) - DISS16(SOAS)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-01) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-08-01) - PSC07
-
gazette-notice-compulsory (2023-09-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-21) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-01-22) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-25) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-01-04) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-01-12) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-01) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-31) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-29) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-17) - NEWINC