-
OMG PROPERTIES 2014 LTD - Marsh Close Gowdall Lane, Snaith, Goole, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09263857
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Marsh Close Gowdall Lane
- Snaith
- Goole
- North Yorkshire
- DN14 0AA
- England Marsh Close Gowdall Lane, Snaith, Goole, North Yorkshire, DN14 0AA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Nigel Weston
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.10.2014
- Gelöscht am:
- 2021-12-21
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nigel Weston Smith
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-12
- Letzte Einreichung: 2020-10-29
-
OMG PROPERTIES 2014 LTD Firmenbeschreibung
- OMG PROPERTIES 2014 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09263857. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Marsh Close Gowdall Lane erreicht werden.
Jetzt sichern OMG PROPERTIES 2014 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Omg Properties 2014 Ltd - Marsh Close Gowdall Lane, Snaith, Goole, North Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OMG PROPERTIES 2014 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-09-27) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-10-05) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-12-21) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-29) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-29) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-29) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-28) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-11-21) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-27) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-07-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-22) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-06-21) - CH03
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-23) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-10-25) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-14) - NEWINC