-
GREEN WORLD SOLUTIONS LTD - Mss House Bankfield Road, Tyldesley, Manchester, M29 8QH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09260261
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mss House Bankfield Road
- Tyldesley
- Manchester
- M29 8QH
- England Mss House Bankfield Road, Tyldesley, Manchester, M29 8QH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HALL, Gerard Francis
- OWEN, Mark Terence
- MARTIN-HALL, Vicki Ann
- Prokuristen
- MARTIN HALL, Vicki Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-13 9 Jahre
- SIC/NACE
- 46900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- One Electrical Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-18
- Letzte Einreichung: 2022-09-04
-
GREEN WORLD SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- GREEN WORLD SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09260261. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Mss House Bankfield Road erreicht werden.
Jetzt sichern GREEN WORLD SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Green World Solutions Ltd - Mss House Bankfield Road, Tyldesley, Manchester, M29 8QH, Grossbritannien
- 2014-10-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREEN WORLD SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-05-25) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-10-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-07) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-06-24) - AA01
-
capital-allotment-shares (2020-07-02) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-20) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-12-16) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-16) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-01) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-06) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-01-04) - AA
-
legacy (2019-01-04) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-01-04) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-01-04) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-10-29) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-29) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-02-22) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-19) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-29) - TM02
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-03-06) - SH02
-
legacy (2018-01-03) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-01-03) - AA
-
legacy (2018-01-03) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-01-03) - AGREEMENT2
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-01-08) - GUARANTEE2
-
legacy (2017-01-08) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-01-08) - AA
-
legacy (2017-01-08) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-25) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-20) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-02-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-22) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-04) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-11-04) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-04) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-13) - NEWINC