-
TEMPUS ENERGY TECHNOLOGY LTD - C/O Leonard Curtis Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09255104
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Leonard Curtis Sophia House
- 28 Cathedral Road
- Cardiff
- CF11 9LJ C/O Leonard Curtis Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ UK
Management
- Geschäftsführung
- BELL, Sara Louise
- SHARP, Garry Macdonald
- WEBB, Molly Wadhams
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-08 9 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Sara Louise Bell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 875500LHUHFINHVMAZ35
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-01
- Letzte Einreichung: 2019-10-20
-
TEMPUS ENERGY TECHNOLOGY LTD Firmenbeschreibung
- TEMPUS ENERGY TECHNOLOGY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09255104. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Leonard Curtis Sophia House erreicht werden.
Jetzt sichern TEMPUS ENERGY TECHNOLOGY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tempus Energy Technology Ltd - C/O Leonard Curtis Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ, Grossbritannien
- 2014-10-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TEMPUS ENERGY TECHNOLOGY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-11-27) - AM10
-
liquidation-in-administration-proposals (2020-03-04) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-13) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2020-01-10) - AM01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2020-03-25) - AM07
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-08-20) - AM10
-
liquidation-in-administration-court-order-ending-administration (2020-11-27) - AM25
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2020-12-15) - COCOMP
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2020-12-15) - WU04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-01) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-15) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-10-13) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-01) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-02-16) - RP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-26) - AD01
-
resolution (2016-02-09) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-01-12) - RP04
-
resolution (2016-01-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-01-08) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-01-06) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-01-06) - SH08
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-01-04) - RP04
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-03-10) - SH01
-
capital-allotment-shares (2015-03-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-06) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-23) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-11-04) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-08) - NEWINC