-
GREENHILL INDUSTRIES LIMITED - The Denby Suite, Sheepbridge Business Centre, Sheffield Road, Chesterfield, S41 9ED, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09251855
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Denby Suite, Sheepbridge Business Centre
- Sheffield Road
- Chesterfield
- S41 9ED
- England The Denby Suite, Sheepbridge Business Centre, Sheffield Road, Chesterfield, S41 9ED, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DYKES, Simon Grant
- DYKES, Charlotte Rebecca
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-07 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Grant Dykes
- Mrs Anne Susan Dykes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- BRABCO 1412 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-09-30
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-18
- Letzte Einreichung: 2023-05-04
-
GREENHILL INDUSTRIES LIMITED Firmenbeschreibung
- GREENHILL INDUSTRIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09251855. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.10.2014 registriert. GREENHILL INDUSTRIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BRABCO 1412 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Denby Suite, Sheepbridge Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern GREENHILL INDUSTRIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greenhill Industries Limited - The Denby Suite, Sheepbridge Business Centre, Sheffield Road, Chesterfield, S41 9ED, Grossbritannien
- 2014-10-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREENHILL INDUSTRIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-04-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-09-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-10-20) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-19) - PSC04
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-10-17) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-10-17) - SH08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-26) - AA
-
memorandum-articles (2020-10-20) - MA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-11) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-16) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-13) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-27) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-04-19) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-31) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-24) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-01-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-29) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-29) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-30) - CERTNM
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-02-22) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-02-22) - SH10
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-29) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-20) - AR01
-
resolution (2015-02-22) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-02-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-07) - NEWINC