-
BIOGAS MEDEN LTD. - 10-12 Frederick Sanger Road, Guildford, GU2 7YD, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09241453
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 10-12 Frederick Sanger Road
- Guildford
- GU2 7YD
- England 10-12 Frederick Sanger Road, Guildford, GU2 7YD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FIELD, Benjamin Thomas
- MEZZULLO, William
- TANNER, Christopher James
- Prokuristen
- FUTURE BIOGAS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Jlen Environmental Assets Group (Uk) Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GAULTNEY HOLDCO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-14
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
-
BIOGAS MEDEN LTD. Firmenbeschreibung
- BIOGAS MEDEN LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09241453. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.09.2014 registriert. BIOGAS MEDEN LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GAULTNEY HOLDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35210" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 10-12 Frederick Sanger Road erreicht werden.
Jetzt sichern BIOGAS MEDEN LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Biogas Meden Ltd. - 10-12 Frederick Sanger Road, Guildford, GU2 7YD, England, Grossbritannien
- 2014-09-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BIOGAS MEDEN LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-11) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2021-01-18) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-04-27) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-06-10) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-04-29) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-16) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-04-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
legacy (2018-10-07) - AGREEMENT2
-
legacy (2018-10-07) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-10-07) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-10-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-20) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-20) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-20) - PSC02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-12-20) - AP04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-11-06) - AA
-
legacy (2017-11-06) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-27) - CS01
-
legacy (2017-10-12) - AGREEMENT2
-
legacy (2017-11-06) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-08) - TM01
-
capital-allotment-shares (2016-06-13) - SH01
-
legacy (2016-07-01) - PARENT_ACC
-
legacy (2016-05-09) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2016-07-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-17) - CS01
-
legacy (2016-07-18) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-12) - AP01
-
dissolution-application-strike-off-company (2015-03-24) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2015-03-31) - GAZ1(A)
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2015-04-24) - DS02
-
change-of-name-notice (2015-08-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-08-10) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-06) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-12) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-10-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-30) - NEWINC