-
SCH 2014 LIMITED - 92, London Street, Reading, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09237593
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 92
- London Street
- Reading
- Berkshire
- RG1 4SJ 92, London Street, Reading, Berkshire, RG1 4SJ UK
Management
- Geschäftsführung
- BINNS, Robert Hugh
- BROWN, Adam John Witherow
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-26 9 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Access Uk Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-10
- Letzte Einreichung: 2019-09-26
-
SCH 2014 LIMITED Firmenbeschreibung
- SCH 2014 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09237593. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.09.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 92 erreicht werden.
Jetzt sichern SCH 2014 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sch 2014 Limited - 92, London Street, Reading, Berkshire, Grossbritannien
- 2014-09-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SCH 2014 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-19) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-13) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-20) - MR04
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-02-18) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-02-18) - 600
-
resolution (2020-02-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-25) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-25) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-02) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-27) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-04-19) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-04-19) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-03-31) - AA01
-
resolution (2017-03-23) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-03-22) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-03-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-11) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-21) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-17) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-02-23) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-23) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-24) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-06-21) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-01) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-12-04) - SH01
-
resolution (2016-12-04) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-05) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-01) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-11) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-01-22) - SH01
-
resolution (2015-01-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-26) - NEWINC