-
SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED - 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09233795
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Moorgate
- London
- EC2R 6AY 25 Moorgate, London, EC2R 6AY UK
Management
- Geschäftsführung
- MOFFITT, John Richard
- TURNER, Christopher David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-24 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sheds General Partner 2 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- CITRUZ GP NOMINEE CO 1 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-10-08
- Letzte Einreichung: 2017-09-24
-
SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED Firmenbeschreibung
- SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09233795. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.09.2014 registriert. SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CITRUZ GP NOMINEE CO 1 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 Moorgate erreicht werden.
Jetzt sichern SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sheds Gp Nominee Co 1 Limited - 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
- 2014-09-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SHEDS GP NOMINEE CO 1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-07-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-07-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-05-22) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-23) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-08) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-09) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-10) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-01) - MR04
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-05-22) - LIQ01
-
resolution (2018-05-22) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-05) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-05) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-05) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-09) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-06) - MR04
-
resolution (2017-10-06) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-05) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-01-13) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-21) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-11) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-07) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-07) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed (2014-12-04) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-29) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-28) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-25) - MR01
-
resolution (2014-11-19) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2014-11-17) - MA
-
resolution (2014-11-17) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2014-09-24) - NEWINC