-
STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED - Berkshire House 168-173 High Holborn, London, WC1V 7AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09227451
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Berkshire House 168-173 High Holborn
- London
- WC1V 7AA Berkshire House 168-173 High Holborn, London, WC1V 7AA UK
Management
- Geschäftsführung
- GEATER, Sara Kate
- LAMBERT, Stephen
- MCMULLEN, Angela
- TURTON, Victoria Jane
- Prokuristen
- MCMULLEN, Angela
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-19 9 Jahre
- SIC/NACE
- 59113
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- All3media Finance Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- NEWINCCO 1329 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-23
- Letzte Einreichung: 2023-10-09
-
STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED Firmenbeschreibung
- STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09227451. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.09.2014 registriert. STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEWINCCO 1329 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59113" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Berkshire House 168-173 High Holborn erreicht werden.
Jetzt sichern STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Studio Lambert Associates Limited - Berkshire House 168-173 High Holborn, London, WC1V 7AA, Grossbritannien
- 2014-09-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STUDIO LAMBERT ASSOCIATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-05-01) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-05-01) - PSC02
keyboard_arrow_right 2023
-
legacy (2023-10-16) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-10-16) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-10-16) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-10-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-02-07) - TM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-08-22) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
court-order (2021-11-05) - OC
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-10-03) - AA
-
(2021-01-04) - ANNOTATION
-
legacy (2021-01-04) - ANNOTATION
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2020-07-15) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-07) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-09-19) - AP03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-07-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-09-29) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-16) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-23) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-08-05) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-12) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-12) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-11-13) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-25) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-01-20) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-03-25) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-24) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-03-04) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-03-04) - SH08
-
resolution (2015-02-24) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-20) - CERTNM
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-01-20) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-20) - AD01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-01-20) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-20) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-01-20) - SH02
-
capital-allotment-shares (2015-01-20) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-11-03) - SH01
-
incorporation-company (2014-09-19) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-14) - AP01