-
BLUE CASTLE (2015) LIMITED - Unit 7 Withambrook Park Industrial Estate, Grantham, NG31 9ST, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09225721
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 7 Withambrook Park Industrial Estate
- Grantham
- NG31 9ST
- England Unit 7 Withambrook Park Industrial Estate, Grantham, NG31 9ST, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HARLEY, Darren Michael
- HARLEY, Marie
- JOHNSON, Adam
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.09.2014
- Gelöscht am:
- 2023-06-27
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mrs Marie Harley
- Mrs Marie Harley
- Hc1234 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-08
- Letzte Einreichung: 2022-11-24
-
BLUE CASTLE (2015) LIMITED Firmenbeschreibung
- BLUE CASTLE (2015) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09225721. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.09.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 7 Withambrook Park Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE CASTLE (2015) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue Castle (2015) Limited - Unit 7 Withambrook Park Industrial Estate, Grantham, NG31 9ST, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE CASTLE (2015) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-04-19) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-08-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-30) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-30) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-24) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-01-17) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-23) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-27) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-20) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-11-20) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-06-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-27) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-23) - AP03
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-02-10) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-24) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-18) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-03) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-10-10) - SH01
-
incorporation-company (2014-09-19) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-18) - TM01