-
54 ESTATES LTD - New Burlington House, 1075 Finchley Road, London, NW11 0PU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09176755
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- New Burlington House
- 1075 Finchley Road
- London
- NW11 0PU
- United Kingdom New Burlington House, 1075 Finchley Road, London, NW11 0PU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- LOW, Sam
- Prokuristen
- LOW, Abraham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-14 9 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Stellacorp Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-29
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-28
- Letzte Einreichung: 2023-08-14
-
54 ESTATES LTD Firmenbeschreibung
- 54 ESTATES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09176755. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.08.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über New Burlington House erreicht werden.
Jetzt sichern 54 ESTATES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 54 Estates Ltd - New Burlington House, 1075 Finchley Road, London, NW11 0PU, Grossbritannien
- 2014-08-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 54 ESTATES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-09) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-01-11) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-11) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-01-11) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-04-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-13) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-27) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-27) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-27) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-13) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-06-29) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-20) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-03-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-18) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-04) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-08) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-01) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-30) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-08-14) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-co-extend-charge-number-charge-creation-date (2014-11-25) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-19) - AP01