-
BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED - Allan House, John Princes Street, London, W1G 0JW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09138056
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Allan House
- John Princes Street
- London
- W1G 0JW
- England Allan House, John Princes Street, London, W1G 0JW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- VERJEE, Simon Saleh
- Prokuristen
- VERJEE, Simon Saleh
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.07.2014
- Gelöscht am:
- 2022-08-23
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Brooksplace Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- 12 GREEK STREET LEEDS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-29
- Letzte Einreichung: 2019-07-18
-
BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED Firmenbeschreibung
- BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09138056. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.07.2014 registriert. BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 12 GREEK STREET LEEDS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Allan House erreicht werden.
Jetzt sichern BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brooksplace (Telephone House) Colchester Limited - Allan House, John Princes Street, London, W1G 0JW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BROOKSPLACE (TELEPHONE HOUSE) COLCHESTER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-24) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-13) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-08-29) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-08-29) - 600
-
resolution (2019-08-29) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-07-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-12) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-25) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-07) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-09-07) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-07) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-06) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-05) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-22) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-10) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-09-06) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-13) - AD01
-
change-of-name-notice (2015-04-25) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-25) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-12) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-06-09) - AP03
-
capital-allotment-shares (2015-10-15) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-18) - NEWINC