-
CONSOLE LOWCO LIMITED - Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09125126
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 10
- Silverglade Business Park
- Leatherhead Road
- Chessington
- Surrey
- KT9 2QL Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2QL UK
Management
- Geschäftsführung
- CULLETON, Helen Mary
- GORDON, James David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.07.2014
- Gelöscht am:
- 2021-03-30
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- A6 Audio Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-24
- Letzte Einreichung: 2020-07-10
-
CONSOLE LOWCO LIMITED Firmenbeschreibung
- CONSOLE LOWCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09125126. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 10 erreicht werden.
Jetzt sichern CONSOLE LOWCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Console Lowco Limited - Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONSOLE LOWCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-01-05) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-01-12) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-02-06) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-14) - CS01
-
legacy (2020-07-08) - CAP-SS
-
resolution (2020-07-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-06-30) - SH01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-07-08) - SH19
-
legacy (2020-07-08) - SH20
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-28) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-09) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-31) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-16) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-26) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-06-26) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-20) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-07-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-11) - AP01
-
incorporation-company (2014-07-10) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-07-11) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-25) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-02) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-08) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-07-11) - TM02