• UK
  • CONSOLE LOWCO LIMITED - Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
09125126
Firmenstatus
GELÖSCHT
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Unit 10
Silverglade Business Park
Leatherhead Road
Chessington
Surrey
KT9 2QL
Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2QL UK

Management

Geschäftsführung
CULLETON, Helen Mary
GORDON, James David
Prokuristen
-

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
10.07.2014
Gelöscht am:
2021-03-30
SIC/NACE
99999

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
-
A6 Audio Bidco Limited

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
dissolved
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2021-03-31
Letzte Einreichung: 2019-03-31
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2021-07-24
Letzte Einreichung: 2020-07-10

CONSOLE LOWCO LIMITED Firmenbeschreibung

CONSOLE LOWCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09125126. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.07.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 10 erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern CONSOLE LOWCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Console Lowco Limited - Unit 10, Silverglade Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Grossbritannien

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONSOLE LOWCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • dissolution-application-strike-off-company (2021-01-05) - DS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-voluntary (2021-01-12) - GAZ1(A)

    In den Warenkorb
     
  • dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-02-06) - SOAS(A)

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2020-07-14) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2020-07-08) - CAP-SS

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2020-07-08) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2020-06-30) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-07-08) - SH19

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2020-07-08) - SH20

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-28) - PSC02

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-28) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-dormant (2019-12-16) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2019-07-10) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-04) - AA

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-22) - AA

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-08) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2018-07-10) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-full (2017-01-09) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-31) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-16) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-26) - PSC02

    In den Warenkorb
     
  • withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-06-26) - PSC09

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2017-07-11) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-20) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • change-person-director-company-with-change-date (2016-05-15) - CH01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-full (2016-01-10) - AA

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-18) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-20) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2014-07-11) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2014-07-11) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2014-07-10) - NEWINC

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-07-11) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-25) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-02) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-08) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-08) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name (2014-07-11) - TM02

    In den Warenkorb
     

expand_less