-
DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED - Harlequin House, Forde Road, Newton Abbot, TQ12 4BT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09121876
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Harlequin House
- Forde Road
- Newton Abbot
- TQ12 4BT
- England Harlequin House, Forde Road, Newton Abbot, TQ12 4BT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BUCHTA, Susan
- GILBERT, Clive
- MAJEWSKI, David Stephen
- Prokuristen
- OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-08 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- Mr Kamlesh Raichura
- -
- International Dance Supplies Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DANCETEACHER HUB LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-22
- Letzte Einreichung: 2019-07-08
-
DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED Firmenbeschreibung
- DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09121876. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.07.2014 registriert. DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DANCETEACHER HUB LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Harlequin House erreicht werden.
Jetzt sichern DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Danceteacher Conference Limited - Harlequin House, Forde Road, Newton Abbot, TQ12 4BT, Grossbritannien
- 2014-07-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DANCETEACHER CONFERENCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-03) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-02-20) - DS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-14) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-06) - TM01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-02-11) - AP04
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-04-11) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-04-11) - AD03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-06-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-09) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-11-08) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-04) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-04) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-22) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-06-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-12) - MR04
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-12-07) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
-
legacy (2018-06-07) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-06-07) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-06-07) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-20) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-20) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-04-06) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-11) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-11) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-17) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-03) - MR01
-
resolution (2017-12-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-amended-with-accounts-type-micro-entity (2016-12-06) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-08) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-17) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-12) - AP01