-
JMC FOODS LTD - 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09118059
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor Allan House
- 10 John Princes Street
- London
- W1G 0AH
- England 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GODDARD, John Frederick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2014
- Alter der Firma 2014-07-07 9 Jahre
- SIC/NACE
- 46330
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. John Russell Kinder Ma Fca
- Mr. John Goddard
- Mr. John Goddard
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- VALLEY MAID INTERNATIONAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-07-19
- Letzte Einreichung: 2018-07-05
-
JMC FOODS LTD Firmenbeschreibung
- JMC FOODS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09118059. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.07.2014 registriert. JMC FOODS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VALLEY MAID INTERNATIONAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46330" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor Allan House erreicht werden.
Jetzt sichern JMC FOODS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jmc Foods Ltd - 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH, Grossbritannien
- 2014-07-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JMC FOODS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-02-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-31) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-01-17) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-01-17) - 600
-
resolution (2019-01-17) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-10-29) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-10-02) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-02) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-02) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-12) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-24) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-10-17) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-10-14) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-14) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-05) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-01) - AP03
-
resolution (2016-09-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-08-31) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-07-07) - NEWINC