-
BOLONGARO & TREVOR CO. LTD. - 5 Pembroke Buildings 5 Pembroke Buildings, Cumberland Park, Willesden, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09099700
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Pembroke Buildings 5 Pembroke Buildings
- Cumberland Park
- Willesden
- London
- NW10 6RE
- England
- NW10 6RE 5 Pembroke Buildings 5 Pembroke Buildings, Cumberland Park, Willesden, London, NW10 6RE, England, NW10 6RE UK
Management
- Geschäftsführung
- JALIL, Muhammad Omar
- JALIL, Muhammad Arshad
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-24 10 Jahre
- SIC/NACE
- 47710
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Muhammad Arshad Jalil
- Mr Muhammad Omar Jalil
- Mrs Naz Jalil
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-12
- Letzte Einreichung: 2023-03-29
-
BOLONGARO & TREVOR CO. LTD. Firmenbeschreibung
- BOLONGARO & TREVOR CO. LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09099700. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47710" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 5 Pembroke Buildings 5 Pembroke Buildings erreicht werden.
Jetzt sichern BOLONGARO & TREVOR CO. LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bolongaro & Trevor Co. Ltd. - 5 Pembroke Buildings 5 Pembroke Buildings, Cumberland Park, Willesden, London, Grossbritannien
- 2014-06-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOLONGARO & TREVOR CO. LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-04-04) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-03-31) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-25) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-24) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-12-24) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-07) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-28) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-30) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-09) - TM02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-03-02) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-24) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-07-09) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-26) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-18) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-23) - AP01
-
incorporation-company (2014-06-24) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-01) - AP01