-
EAST HAM REGENERATION LIMITED - Dransfield House 2 Fox Valley Way, Fox Valley, Sheffield, S36 2AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09099514
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dransfield House 2 Fox Valley Way
- Fox Valley
- Sheffield
- S36 2AB Dransfield House 2 Fox Valley Way, Fox Valley, Sheffield, S36 2AB UK
Management
- Geschäftsführung
- BARKER, Shaun David
- DRANSFIELD, Mark
- MALLEY, Andrew Christopher
- SUNNUCKS, William D'Urban
- Prokuristen
- STEAD, Steven
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-24 10 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dransfield Properties Ltd
- Land Management Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-06-30
- Letzte Einreichung: 2023-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-08
- Letzte Einreichung: 2023-11-24
-
EAST HAM REGENERATION LIMITED Firmenbeschreibung
- EAST HAM REGENERATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09099514. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Dransfield House 2 Fox Valley Way erreicht werden.
Jetzt sichern EAST HAM REGENERATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: East Ham Regeneration Limited - Dransfield House 2 Fox Valley Way, Fox Valley, Sheffield, S36 2AB, Grossbritannien
- 2014-06-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EAST HAM REGENERATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-06) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-01) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-04) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-07-10) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
-
resolution (2017-07-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-24) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-11-24) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-15) - AP01
-
resolution (2014-08-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-28) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-07-22) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-07-09) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-07-09) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-06-24) - TM01