-
DREAM AGILITY LIMITED - St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09077999
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- St George's House
- 215-219 Chester Road
- Manchester
- M15 4JE St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARK, Elizabeth Melanie
- LILLEY, Derek
- POWDITCH, Glyn Stewart
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-09 9 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Glyn Stewart Powditch
- Ms Elizabeth Melanie Clark
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- JCCO 359 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-30
- Letzte Einreichung: 2017-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-24
- Letzte Einreichung: 2018-08-10
-
DREAM AGILITY LIMITED Firmenbeschreibung
- DREAM AGILITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09077999. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.06.2014 registriert. DREAM AGILITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JCCO 359 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über St George's House erreicht werden.
Jetzt sichern DREAM AGILITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dream Agility Limited - St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE, Grossbritannien
- 2014-06-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DREAM AGILITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-10-06) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-01-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-11-14) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2019-11-05) - AM22
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-06-17) - AM10
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-01-24) - AM02
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2019-01-17) - AM07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-05) - AP01
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-11-27) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-29) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-12-27) - AM07
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-11-26) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-01-05) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-01-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-07-16) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-07-16) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-07-16) - SH02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-01) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-08-06) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-07) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-07-16) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-10-23) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-25) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-25) - TM02
-
certificate-change-of-name-company (2014-09-19) - CERTNM
-
incorporation-company (2014-06-09) - NEWINC