-
NEWBURY NEW BUILD LIMITED - C/O Leigh Adams Limited Maple House, High Street, Potters Bar, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09075168
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Leigh Adams Limited Maple House
- High Street
- Potters Bar
- Hertfordshire
- EN6 5BS C/O Leigh Adams Limited Maple House, High Street, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 5BS UK
Management
- Geschäftsführung
- CROOK, Duncan Timothy
- JONES, Nigel Lawrence
- Prokuristen
- JONES, Nigel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-06 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ressance Limited
- Ressance Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- RESSANCE CONSTRUCTION LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-02
- Letzte Einreichung: 2021-02-16
-
NEWBURY NEW BUILD LIMITED Firmenbeschreibung
- NEWBURY NEW BUILD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09075168. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.06.2014 registriert. NEWBURY NEW BUILD LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RESSANCE CONSTRUCTION LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über C/o Leigh Adams Limited Maple House erreicht werden.
Jetzt sichern NEWBURY NEW BUILD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Newbury New Build Limited - C/O Leigh Adams Limited Maple House, High Street, Potters Bar, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2014-06-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEWBURY NEW BUILD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-02-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-establishment-of-creditors-or-liquidation-committee (2022-01-25) - COM1
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-02-11) - 600
-
resolution (2022-02-11) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-01-09) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-02-09) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-03-10) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-16) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-24) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-12-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-18) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-01-20) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-06-06) - NEWINC