-
DUNNS LANE LIMITED - Flavel House, Caldwell Road, Nuneaton, CV11 4NB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09071198
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Flavel House
- Caldwell Road
- Nuneaton
- CV11 4NB
- England Flavel House, Caldwell Road, Nuneaton, CV11 4NB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WHITTHREAD, Sarah Dawn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-04 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Dunns Lane Group Holding Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- receivership
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-04-30
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-15
- Letzte Einreichung: 2019-04-01
-
DUNNS LANE LIMITED Firmenbeschreibung
- DUNNS LANE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09071198. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Flavel House erreicht werden.
Jetzt sichern DUNNS LANE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dunns Lane Limited - Flavel House, Caldwell Road, Nuneaton, CV11 4NB, Grossbritannien
- 2014-06-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUNNS LANE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-01-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-17) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-17) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-09) - CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-05-15) - RP04SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-10) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-06-06) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2018-09-16) - RM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-06-05) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-12) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-08-12) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-12) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-12) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-12) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-12) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-06-06) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-04) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-04) - PSC07
-
gazette-notice-compulsory (2018-06-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-25) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-26) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-07) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-21) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-03) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-17) - AD01
-
incorporation-company (2014-06-04) - NEWINC