-
SURESCREEN HOLDINGS LIMITED - Lucinda House, 8b Little Oak Drive, Annesley, Nottinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09067025
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lucinda House
- 8b Little Oak Drive
- Annesley
- Nottinghamshire
- NG15 0DR
- England Lucinda House, 8b Little Oak Drive, Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPBELL, Alastair James
- CAMPBELL, Alexander Robert
- CAMPBELL, David Stewart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-02 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Surescreen Holdings (2022) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-16
- Letzte Einreichung: 2023-06-02
-
SURESCREEN HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- SURESCREEN HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09067025. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Lucinda House erreicht werden.
Jetzt sichern SURESCREEN HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Surescreen Holdings Limited - Lucinda House, 8b Little Oak Drive, Annesley, Nottinghamshire, Grossbritannien
- 2014-06-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SURESCREEN HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2023-06-08) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2023-06-08) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-05-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-01-09) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-01-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-06) - AD01
-
resolution (2023-06-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-12-12) - PSC07
-
resolution (2022-10-17) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2022-10-17) - MA
-
capital-name-of-class-of-shares (2022-10-17) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-06-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-06) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-04-22) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-12-12) - PSC02
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-10-04) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-09-25) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-03) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-14) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-08) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-31) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-11-29) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-08) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-02) - MR01
-
capital-allotment-shares (2016-03-10) - SH01
-
resolution (2016-03-10) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-06-02) - NEWINC