-
MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD - Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09064449
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Two Snowhill
- Snow Hill Queensway
- Birmingham
- B4 6GA Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA UK
Management
- Geschäftsführung
- BLACKLAWS, Alistair Campbell
- CLEGG, Darren Grant
- HOLMES, Mark Andrew
- MCCORMACK, Gerard Joseph
- SEYMOUR, Ashley Michael
- WEBB, Jonathan Mark
- WILSON, Andrew Jon
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-30 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alistair Campbell Blacklaws
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- MATRIX PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-02-28
- Letzte Einreichung: 2017-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-10-26
- Letzte Einreichung: 2018-10-12
-
MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD Firmenbeschreibung
- MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09064449. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.05.2014 registriert. MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MATRIX PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Two Snowhill erreicht werden.
Jetzt sichern MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Matrix Medical Properties Ltd - Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
- 2014-05-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MATRIX MEDICAL PROPERTIES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-01-29) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-05-18) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-death-liquidator (2020-12-22) - LIQ09
-
resolution (2020-12-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-01-08) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-01-08) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-12) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-02-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-11-03) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-26) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-02-18) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-09-11) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2015-09-11) - CC04
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-09-11) - SH08
-
capital-allotment-shares (2015-09-11) - SH01
-
capital-allotment-shares (2015-09-07) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-10) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-25) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-11-12) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-25) - CH01