-
REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09056450
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Riverside House
- Irwell Street
- Manchester
- M3 5EN
- England Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOOTH, Daniel John
- CAIN, Gary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Leonard Curtis Recovery Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- FAS PATHSTONE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-10
- Letzte Einreichung: 2023-05-27
-
REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED Firmenbeschreibung
- REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09056450. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.05.2014 registriert. REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FAS PATHSTONE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Riverside House erreicht werden.
Jetzt sichern REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Reach Commercial Finance Limited - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
- 2014-05-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REACH COMMERCIAL FINANCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-12-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-05-31) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-11-18) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-11-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-10-20) - PSC05
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-09-07) - SH08
-
memorandum-articles (2021-09-07) - MA
-
resolution (2021-09-07) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-25) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-01) - CS01
-
resolution (2020-02-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-10) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-28) - AA
-
resolution (2018-10-18) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-02) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-02) - PSC05
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-09-24) - SH08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-25) - AA
-
resolution (2017-08-25) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-03-29) - SH01
-
resolution (2017-03-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-12-04) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-08-09) - SH08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-26) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-01) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-08) - CH01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2015-06-08) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-24) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-08-15) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-08-15) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-08-15) - SH08
-
resolution (2014-08-15) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-06-16) - AA01
-
incorporation-company (2014-05-27) - NEWINC