-
10 BELLS LIMITED - 40 Craven Street, London, WC2N 5NG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09055630
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40 Craven Street
- London
- WC2N 5NG 40 Craven Street, London, WC2N 5NG UK
Management
- Geschäftsführung
- MARRISON, Ashley Charles Meynell
- MOREAU, Ellen Margaret
- Prokuristen
- SOVEREIGN REGISTRARS (ISLE OF MAN) LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-23 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Ms Gill Graham
- Mrs Diane Dentith
- -
- Mrs. Diane Dentith
- Mr Thomas Caulfield
- Mr Howard Thomas Dixon Bilton
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AGHOCO 1227 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-06
- Letzte Einreichung: 2021-05-23
-
10 BELLS LIMITED Firmenbeschreibung
- 10 BELLS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09055630. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.05.2014 registriert. 10 BELLS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGHOCO 1227 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 40 Craven Street erreicht werden.
Jetzt sichern 10 BELLS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 10 Bells Limited - 40 Craven Street, London, WC2N 5NG, Grossbritannien
- 2014-05-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 10 BELLS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-17) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-09) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-27) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2018-05-23) - MR05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-31) - CS01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2018-06-12) - CH04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-28) - TM01
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2018-06-12) - CH02
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-06) - MR04
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-03-28) - AP02
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-31) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-08-15) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-04) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-15) - TM01
-
incorporation-company (2014-05-23) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-29) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-01) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-09-01) - AA01
-
resolution (2014-09-09) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-15) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-15) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2014-09-29) - AP04
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2014-09-29) - AP02
-
memorandum-articles (2014-09-09) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-03) - MR01