-
PANSENSIC LIMITED - Unit 19-, 21 Efford Down Farm Vicarage Road, Bude, Cornwall, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09053940
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 19-
- 21 Efford Down Farm Vicarage Road
- Bude
- Cornwall
- EX23 8LT
- England Unit 19-, 21 Efford Down Farm Vicarage Road, Bude, Cornwall, EX23 8LT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHALLACOMBE, Michael Terence
- HOWARTH, Paul
- DAVEY, Theo Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-23 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Emotionalai Ltd
- Akumen Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PANSENSIC INSIGHT LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-06
- Letzte Einreichung: 2020-05-23
-
PANSENSIC LIMITED Firmenbeschreibung
- PANSENSIC LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09053940. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.05.2014 registriert. PANSENSIC LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PANSENSIC INSIGHT LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 19- erreicht werden.
Jetzt sichern PANSENSIC LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pansensic Limited - Unit 19-, 21 Efford Down Farm Vicarage Road, Bude, Cornwall, Grossbritannien
- 2014-05-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PANSENSIC LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-01) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-05) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-04) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2020-02-04) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-04) - PSC07
-
resolution (2020-01-24) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-04-01) - TM02
-
second-filing-capital-allotment-shares (2020-07-03) - RP04SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-04) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-23) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-22) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-16) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-05-16) - CH03
-
capital-allotment-shares (2018-06-05) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-05) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-05) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-02) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-02) - AA
-
resolution (2018-06-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-07) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-05) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-05-31) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-05-30) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-05-31) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-05-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-01) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-06-24) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-27) - AR01
-
change-of-name-notice (2015-07-02) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-07-02) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-07-03) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-07-03) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-28) - AP01
-
resolution (2015-07-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-07-28) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-31) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-23) - NEWINC