-
SALOP DEVELOPMENTS LIMITED - Astute House, Wilmslow Road, Handforth, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09045516
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Astute House
- Wilmslow Road
- Handforth
- Cheshire
- SK9 3HP Astute House, Wilmslow Road, Handforth, Cheshire, SK9 3HP UK
Management
- Geschäftsführung
- FELL, Robin Wallace
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-19 10 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Robin Fell
- Mr Robin Wallace Fell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-02
- Letzte Einreichung: 2020-05-19
-
SALOP DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- SALOP DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09045516. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Astute House erreicht werden.
Jetzt sichern SALOP DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Salop Developments Limited - Astute House, Wilmslow Road, Handforth, Cheshire, Grossbritannien
- 2014-05-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SALOP DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2022-01-11) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-08) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-11-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-03) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-19) - PSC04
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-02) - 600
-
resolution (2020-12-02) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-23) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-12-02) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-22) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-09) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-03) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-21) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-21) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-30) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-14) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-09-02) - AA01
-
incorporation-company (2014-05-19) - NEWINC